Risultati 1 - 71 di 71
Tabella con righe a strisce.
Ordina in base alle raccolte Uniche all’area geografica New York
Ordina per Conteggio
New York, Stati Uniti, Testamenti e documenti di successione, 1659-1999 (in inglese)5.243.643
Documenti genealogici di New York, 1675-1920 (in inglese)797.866
New York, New York, Stati Uniti, Foto per fini fiscali, 1940 (in inglese)682.866
New York, Stati Uniti, Registri di valutazione delle tasse e proprietà immobiliari e personali, 1799-1804 (in inglese)452.016
New York, Stati Uniti, Registri del governatore relativi alle carcerazioni, 1842-1908 (in inglese)294.322
New York, Stati Uniti, Documenti bancari dei risparmi degli emigranti, 1850-1883 (in inglese)284.268
Stati Uniti, Documenti ricostruiti del censimento, 1660-1820 (in inglese)171.563
Contea di New York, indice delle lettere amministrative, 1743-1875 (Raccolta Barber) (in inglese)92.318
New York, Stati Uniti, Registri di ammissione nella prigione di Sing Sing, 1865-1939 (in inglese)78.507
Stato di New York, Indice di schede relative ai documenti della corte suprema e del tribunale di Chancery, 1648-1848 (in inglese)72.670
New York, Stati Uniti, Ordini esecutivi per commutazioni, grazie, reintegrazioni e sospensioni, 1845-1931 (in inglese)65.371
New York, Stati Uniti, Rilascio dei detenuti, 1882-1915 (in inglese)51.220
Contea di New York, New York, Stati Uniti, Testamenti e documenti di successione, 1658-1880 (NYSA) (in inglese)24.108
New York, Stati Uniti, Società querelanti, 1824-1911 (in inglese)20.399
New York, Stati Uniti, Indice delle pratiche relative all’esclusione di cinesi, 1898-1943 (in inglese)18.564
New York, Documenti dell’istituto penitenziario di Great Meadow, 1911-1933 (in inglese)17.311
Minutes of the Common Council of the city of New York, 1784-1831 (in inglese)14.732
New York, Stati Uniti, Selezione di casi della Corte del sindaco, 1674-1860 (in inglese)9.144
Stato di New York, Registri dei mandati e delle richieste di estradizione, 1857-1938 (in inglese)7.575
New York, Stati Uniti, Libri di ammissione della prigione Clinton, 1851-1866, 1926-1939 (in inglese)5.532
New York, Stati Uniti, Prigionieri ammessi nella prigione di stato di Newgate, 1797-1810 (in inglese)5.198
Minutes of the Common Council of the city of New York, 1675-1776 : in eight volumes. (in inglese)3.766
Selezione di casi di debitori insolventi, 1787-1861 (AJHS) (in inglese)3.497
The records of New Amsterdam from 1653 to 1674 anno Domini (in inglese)2.764
New York, Stati Uniti, American Jewish Joint Distribution Committee, Pagamenti per gli ebrei polacchi, 1915-1918 (in inglese)2.396
Journal of the Legislative Council of the colony of New-York (in inglese)2.105
Stati Uniti, Cause giudiziarie criminali di tribunali circoscrizionali, 1790-1871 (in inglese)2.057
The Historic annals of southwestern New York (in inglese)2.033
Historical miscellany (in inglese)2.005
New York, Stati Uniti, Inventari e conti delle proprietà, 1666-1822 (in inglese)1.104
Western New York Land Transactions, 1825-1835 (in inglese)811
Long Island Source Records (in inglese)747
New York Wills, 1626-1836 (in inglese)673
Colonial charters, patents and grants to the communities comprising the city of New York (in inglese)665
New York, Stati Uniti, Vendite delle terre dei lealisti, 1762-1830 (in inglese)575
Index of wills for New York County, New York from 1851 to 1875, inclusive (in inglese)532
Index of wills for New York County (New York City) from 1662-1850 (in inglese)498
Western New York Land Transactions, 1804-1824 (in inglese)489
Official minutes of the New York Commercial Tercentary Commission (in inglese)475
Annals of Staten Island : from its discovery to the present time (in inglese)472
Historic Homes and Institutions and Genealogical and Family History of New York, Vol. II (in inglese)372
Harvard Club of New York City: constitution, by-laws, rules and list of officers and members. (in inglese)351
Historic Homes and Institutions and Genealogical and Family History of New York, Vol. IV (in inglese)340
Index of Wills Probated in Kings County, New York (in inglese)336
Minutes of the Town Courts of Newtown: 1656-1690 (in inglese)333
Historic Homes and Institutions and Genealogical and Family History of New York, Vol. I (in inglese)328
The Brooklyn Compendium (in inglese)324
Historic Homes and Institutions and Genealogical and Family History of New York, Vol. III (in inglese)302
The Thousand Islands of the River St. Lawrence (in inglese)302
English crown grants (in inglese)275
Documents and letters intended to illustrate the revolutionary incidents of Queens County (in inglese)262
Select patents of New York towns (in inglese)242
Landholders of Northeastern New York, 1739-1802 (in inglese)230
Long Island colonial patents (in inglese)198
Report of the Joint Committee on the Centennial Celebration of the Evacuation of New York by the British (in inglese)191
Record of real estate owned by the city of New York (in inglese)184
Abstracts of Van Voorhees family wills in the Surrogate's Office of New York County (in inglese)173
Wills of the Smith families of New York and Long Island, 1664-1794 (in inglese)166
New York, Stati Uniti, American Jewish Joint Distribution Committee, Pagamenti per gli ebrei rumeni, 1917-1918 (in inglese)149
New York Alien Residents, 1825-1848 (in inglese)126
Records in the office of the county clerk at Jamaica, Long Island, New York (in inglese)122
Southold Connections (in inglese)118
List of persons who were taxed on seventeen thousand five hundred dollars and upwards in the city of New York (in inglese)99
New York, Stati Uniti, American Jewish Joint Distribution Committee, Pagamenti per gli ebrei russi, 1916-1917 (in inglese)98
Titles to land and land under water at Sea Gate, New York Harbor (in inglese)93
Miscellaneous material (in inglese)92
Abstract of wills probated in the Common Pleas Court (in inglese)71
Report on examination of personnel, methods of work and equipment of the Department of Street Cleaning, New York City (in inglese)47
Notes on the patroonships, manors and seigneuries in colonial times (in inglese)43
Minority report of the New York Charter Commission created by chapter 343 of the Laws of 1921, with proposed Home Rule Charter (in inglese)38
Save the City Hall and the City Hall Park (in inglese)15

Passa a tutte le raccolte che sono correlate all’area geografica New York