Risultati 1 - 100 di 127
Tabella con righe a strisce.
Ordina in base alle raccolte Correlate all’area geografica Maine
Ordina per Conteggio
Stati Uniti, Elenchi cittadini, 1822-1995 (in inglese)1.385.585.010
Annuari delle scuole americane, 1900-2016 (in inglese)881.226.614
Stati Uniti, Archivio di documenti pubblici, 1950-1993, Volume 1 (in inglese)418.676.059
Stati Uniti, Archivio di documenti pubblici, 1950-1993, Volume 2 (in inglese)402.455.530
Stati Uniti, Archivi di documenti pubblici, 1994-2019 (in inglese)330.831.845
Stati Uniti, Elenchi telefonici e di indirizzi, 1993-2002 (in inglese)313.273.297
Cataloghi delle scuole americane, 1754-1986 (in inglese)5.378.762
Registro ufficiale degli Stati Uniti, 1863-1959 (in inglese)3.783.772
Archivi del Regno Unito e negli Stati Uniti, 1680-1830 (in inglese)2.518.462
USA, Elenchi di studenti universitari, 1763-1924 (in inglese)1.516.361
Stati Uniti, Archivio delle pensioni delle ferrovie, 1934-1987 (in inglese)1.514.828
Cariche di direttore di ufficio postale degli Stati Uniti, 1832-1971 (in inglese)1.514.110
Stati Uniti, Elenchi di studenti, 1821-1923 (in inglese)645.940
Stati Uniti, Annuari ed elenchi dei laureati delle università quacchere, 1911-1940 (in inglese)521.947
Web: Stati Uniti, Incidenti minerari, 1839-2006 (in inglese)520.498
Stati Uniti, Archivi di schede del corpo delle infermiere cadette della seconda guerra mondiale, 1942-1948 (in inglese)390.020
New England, Selezione di documenti della Chiese Metodista Unita,1787-1922 (in inglese)374.894
Stati Uniti, Enciclopedia della genealogia dei quaccheri americani, Vol I–VI, 1600-1900 (in inglese)356.712
Stati Uniti, Registro nazionale del personale scientifico e tecnico, 1921-1970 (in inglese)320.834
Maine, U.S., City Directories (in inglese)170.315
Stati Uniti, Questionari del baseball, 1945-2005 (in inglese)154.715
Directory of Deceased American Physicians, 1804-1929 (in inglese)148.655
Stati Uniti, Documenti della migrazione mormone, 1840-1932 (in inglese)143.658
Stati Uniti, Estratti delle minute delle riunioni annuali dei Quaccheri, 1808-1930 (in inglese)116.253
Documenti anagrafici SUG, Appartenenza alla Chiesa di Gesù dei Santi degli Ultimi Giorni, 1830-1848 (in inglese)104.231
Minnesota, Stati Uniti., Documenti delle adesioni al Sons of Norway 1737-1970 (in inglese)90.584
Stati Uniti, Archivio dei necrologi dei quaccheri, 1822-2012 (in inglese)79.196
Stati Uniti, Schede di servizio di operatori ospedalieri, caposala e infermiere, 1861-1865 (in inglese)73.588
Elenchi: Portland, Maine, 1889-91 (in inglese)65.403
Copia del censimento, indice genealogico, 1890 (in inglese)63.405
Stati Uniti e Regno Unito, Memoriali pubblicati dai Quaccheri, 1818-1919 (in inglese)55.135
Bangor, Maine, Stati Uniti, Elenchi cittadini, 1882-1892 (in inglese)52.580
Stati Uniti, Genealogie quacchere, 1893-2003 (in inglese)31.254
Web: Stati Uniti, Archivio dei certificati di protezione dei marinai, 1796-1871 (in inglese)29.384
Elenco: Lewiston, Androscoggin County, Maine,, 1908 (in inglese)26.324
I primi membri della Chiesa Riorganizzata di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (in inglese)25.973
Stati Uniti, Documenti compilati da diverse società, 1875-2010 (in inglese)22.086
Stati Uniti, Storie pubblicate delle famiglie quacchere (in inglese)17.950
Giocatori professionisti di baseball, 1876-2004 (in inglese)13.622
Elenco biografico del Congresso degli Stati Uniti, 1774-2005 (in inglese)12.184
U.S., Sons of the American Revolution, 1783-1902 (in inglese)10.909
Indice dei fabbri e dei mestieri correlati, 1720-1940 (in inglese)9.916
Stati Uniti, Membri dell’American Protective League, 1917-1919 (in inglese)8.804
Elenco: Presbyterian Ministerial, 1898 (in inglese)8.484
Georgia, Stati Uniti, Documenti e schede di imbarco dei missionari battisti, 1814-1970 (in inglese)8.068
Elenco: Biddeford, Maine, 1890-91 (in inglese)7.395
Elenchi del Motion Picture Studio, 1919 e 1921 (in inglese)6.707
Area di Augusta, Maine, Stati Uniti, Elenco, 1882 (in inglese)6.245
Elenco del clero della chiesa protestante episcopale, Stati Uniti, 1898 (in inglese)5.054
Elenco: Lewiston & Auburn, Androscoggin County, Maine, 1860, (in inglese)4.009
Nord America, Archivio delle riunioni mensili dei Quaccheri, 1671-2010 (in inglese)2.087
Stati Uniti, Archivi di schede di identificazione degli agenti del proibizionismo, 1920-1925 (in inglese)1.772
Stati Uniti, Pratiche relative alle infermiere della Croce Rossa americana della prima guerra mondiale, 1916-1959 (in inglese)1.491
Williams' Cincinnati directory (in inglese)1.334
Compendio degli autori americani, 1907 (in inglese)930
Harvard alumni directory, 1919 (in inglese)803
Obituary record of the graduates of Bowdoin College and the Medical School of Maine for the decade ending 1 June 1909 (in inglese)510
Memorials of the introduction of Methodism into the eastern states (in inglese)487
An apology for African Methodism (in inglese)475
A Brief History of the Lutheran Church in America (in inglese)467
The New-York annual register for the year of our Lord 1834 (in inglese)446
Stati Uniti, Archivio dei cognomi nei documenti dei Quaccheri (in inglese)444
Highways and hedges, or, Fifty years of western Methodism (in inglese)396
Friends of a half century : fifty memorials with portraits of members of the Society of Friends, 1840-1890 (in inglese)389
The Maine register and business directory for the year 1856 (in inglese)360
Directory of the cities of Augusta, Hallowell and Gardiner for 1882 (in inglese)338
A history of the German Congregational churches in the United States (in inglese)328
The town register, East Livermore, Livermore, Jay, 1909 (in inglese)302
The Colonial Clergy and the Colonial Churches of New England (in inglese)281
A History of the Wedgwood Family (in inglese)272
The Town register, Farmington, Wilton, Chesterville, New Sharon (in inglese)271
The town register, Wayne, Wales, Monmouth, Leeds, Greene : 1905 (in inglese)255
Twenty years at Pemaquid : sketches of its history and its remains, ancient and modern (in inglese)253
The town register, Islesboro, Castine, Penobscot, Brooksville, 1906 (in inglese)247
The town register, Gorham and Buxton, 1905 (in inglese)233
Scenes in a vestry : being an account of the late controversy in the South Parish Congregational Church in Augusta (in inglese)232
The Lewiston and Auburn directory : containing the names of the inhabitants, their occupation and places of business, &c., the (in inglese)217
Founding and organization of the Daughters of the American Revolution and Daughters of the Revolution (in inglese)206
History of the State Normal School, Farmington, Maine : with sketches of the teachers and graduates (in inglese)203
Cyclopaedia of African Methodism (in inglese)198
Family notes and reminiscences (in inglese)191
Directory of churches and religious organizations in Maine (in inglese)171
The Town Register, Otisfield, Harrison, Naples and Sebago: 1906 (in inglese)169
Peirce's Colonial Lists (in inglese)159
Resident and business directory of the town of Brunswick and Topsham village, with maps (in inglese)157
Christ Church, Gardiner, Maine : antecedents and history (in inglese)156
Quaker Arrivals at Philadelphia 1682-1750 (in inglese)137
Souvenir and directory of the St. Paul Presbyterian Church of Philadelphia (in inglese)136
Register of the St. Albans Presbyterian Church : organized August 22, 1868 : Seventh Avenue and E Street, St. Albans, W. Va. (in inglese)129
A centennial discourse delivered to the First Congregational Church and Society in Leominster, September 24, 1843 (in inglese)114
The Webster, West Gardiner, Litchfield, and Monmouth register, 1909 (in inglese)104
Remembering the days of old, or, The Puritans and their descendants (in inglese)97
History of the Park Ridge schools, 1808 to 1938 (in inglese)96
Appleton register, 1903 : containing history, date of birth of all residents, deaths : business directory (in inglese)95
Historical sketch of the Congregational church and parish of Canton Center, Conn. (in inglese)94
First annual gathering of the Clan MacLean Association of North America : held in the city of Chicago, June 12-16, 1893 (in inglese)83
The Milbridge register, 1905 (in inglese)79
The centennial of the Cumberland Association of Congregational Ministers (in inglese)78
Historical sketch and principles and regulations, with a list of former and present members of the First Congregational Church, Farmington, Maine (in inglese)78
Celebration of the two hundred and fiftieth anniversary of the landing of Samuel Packard in this country, August 10, 1638 (in inglese)73

Passa a tutte le raccolte che sono uniche all’area geografica Maine